喜願建設股份有限公司 Approved
最後更新時間 2025/07/10 , 03:04 PM
最後更新時間 2025/07/10 , 03:04 PM
負責人
Jian,Gong-Hao
統一編號
16004431
成立日期
1997/05/16
資本額
NT$50,000,000
實收資本額
NT$10,000,000
股票代號
電話
06-2656232#63
地址
2F, No. 259, Sindu Rd., South Dist., Tainan City, 702, Taiwan
網站
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
Jian,Gong-Hao Chairman 100.00% XIN YI INVESTMENT CO., LTD.
Chen,Yi-Han Supervisor 100.00% XIN YI INVESTMENT CO., LTD.
營業項目
  • Construction of Buildings(410016)
  • Real Estate Development Activities(670012)
  • 公司歷程
  • Change Capital to 50,000,000
    2021/03/30
  • Change Person in Charge to Jian,Gong-Hao
    2021/03/30
  • Change Person in Charge to Chen,Chun-Tian
    2018/08/27
  • Change Person in Charge to Lin,Wen-Qi
    2017/10/17
  • Change Person in Charge to Zhu,Guo-Rong
    2015/10/02
  • 員工人數
    下載完整報告查看完整數據
    財務報表
    動產抵押
    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額
    標案拒往
    機關名稱 生效日期 截止日期
    進出口資料
    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    商標
  • 天都金寶塔
  • 喜願建設天都禪寺金剛舍利寶塔Ten Du Chan Monastery
  • 天都金剛舍利寶塔
  • 天都
  • 喜願
  • 天都禪寺
  • 喜願設計圖
  • 天都禪寺金寶塔
  • 專利
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
  • Others
    2013, 2015
  • Pay off debt
    2014
  • Pay off loan
    2018
  • Litigation aid
    2017
  • Loan repayment
    2023
  • Pay the ticket
    2005
  • Stop execution
    2014
  • Pay salary, etc.
    2019
  • Auction collateral
    2007, 2012
  • Motion of objection
    2014
  • Provisional injunction
    2006
  • Debtor objection appeal
    2014, 2015
  • Pay severance pay, etc.
    2018, 2019, 2020
  • Return security deposit
    2024
  • Determine legal expenses
    2014
  • Time-limited prosecution
    2013, 2014, 2017
  • Pay for liquidated damages
    2013
  • Third party objection suit
    2014
  • Division of common property
    2009
  • Pay telecommunication charges
    2018
  • Promissory note ruling enforcement
    2008, 2012, 2013, 2014, 2019
  • Ruling of legal expenses ex officio
    2020
  • Exercising rights within a time limit
    2023
  • Confirmation of the non-existence of sale relationship
    2008
  • Others
    2005, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2022, 2023
  • Forgery
    2022, 2023
  • Pay rent
    2018
  • Pay off loan
    2018
  • Payment order
    2011, 2018
  • Pay the ticket
    2005, 2014
  • Return deposit
    2016
  • Stop execution
    2013, 2014
  • Pay salary, etc.
    2019, 2020, 2021
  • Auction collateral
    2012, 2013
  • Petition for trial
    2013
  • Motion of objection
    2015, 2016
  • Trademark Evaluation
    2014
  • Business encroachment
    2022
  • Promissory note ruling
    2011
  • Debtor objection appeal
    2016, 2017
  • Pay severance pay, etc.
    2020
  • Request for salary, etc.
    2023
  • Forgery of documents, etc.
    2022
  • Pay for liquidated damages
    2012, 2013
  • Division of common property
    2009, 2010, 2011, 2013, 2014
  • Funeral Management Regulations
    2008, 2010, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023
  • Refund on behalf of the advance
    2015, 2017, 2019, 2020
  • Request for damage compensation
    2018
  • Promissory note ruling enforcement
    2013, 2014
  • Confirmation of the non-existence of sale relationship
    2008
  • Confirmation of the non-existence of promissory note, etc
    2012, 2013
  • 勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。