林德台灣科技股份有限公司 Approved
最後更新時間 2025/07/11 , 07:30 AM
最後更新時間 2025/07/11 , 07:30 AM
統一編號
16836337
成立日期
1999/02/11
資本額
NT$192,975,070
實收資本額
NT$192,975,070
股票代號
電話
03-5543538
地址
No. 217-1, Sec. 2, Zihciang Rd., Toufen City, Miaoli County, 351, Taiwan
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
Jochen Christopher Buetzler Chairman 51.00% Linde Inc.
Jeremy Rae Harris Director 51.00% Linde Inc.
Chen,Rui-Long Director 33.00% CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORPORATION
Mayur Agarwal Supervisor 0.00%
營業項目
  • Gas Supply(352000)
  • Wholesale of Liquid, Gaseous Fuels and Related Products(463112)
  • Retail Sale of Other Fuel and Related Products in Specialized Stores(482912)
  • Wholesale of Other Machinery and Equipment(464999)
  • 公司歷程
  • Change Person in Charge to JochenChristopherBuetzler
    2024/06/26
  • Change Person in Charge to Wei Nuo,Yi-Fan-Si
    2024/05/24
  • Change Person in Charge to VernonThadEvans
    2022/02/09
  • Change Person in Charge to (VernonThadEvans)
    2017/07/06
  • Change Person in Charge to Wei Nuo,Yi-Fan-Si
    2016/04/28
  • Change Person in Charge to (VernonThadEvans)
    2015/11/12
  • Change Person in Charge to Lin,Ke-Ming
    2014/11/14
  • Change Person in Charge to
    2013/01/30
  • 員工人數
    下載完整報告查看完整數據
    財務報表
    動產抵押
    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額
    標案拒往
    機關名稱 生效日期 截止日期
    進出口資料
    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    商標
    專利
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
  • Others
    2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
  • Pay rent
    2017
  • Company dissolution
    2013
  • Preservation of evidence
    2017
  • Appointment of inspectors
    2017
  • Discretionary Inspector Remuneration
    2022
  • Appointment of interim administrators
    2017
  • Peition for punishment of temporary status
    2021
  • Revocation of resolutions of shareholders' meeting
    2013, 2015, 2016
  • Confirmation that the resolution of the shareholders' meeting is invalid, etc.
    2018
  • Others
    2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022
  • Pay rent
    2018
  • Company Law
    2015, 2016, 2017
  • Payment order
    2009
  • Pay for the goods
    2009
  • Return seal stamp
    2017
  • Petition for trial
    2017
  • Petition for stopage
    2017
  • Invalidating Judgment
    2001
  • Petition filed for public summons
    2007
  • Revocation of resolutions of shareholders' meeting
    2016, 2017
  • Confirmation of the non-existence of appointment relationship
    2013, 2014
  • Confirmation that the resolution of the shareholders' meeting is invalid, etc.
    2019, 2022
  • 勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。