台灣房屋仲介股份有限公司 Approved
最後更新時間 2025/07/21 , 03:15 AM
最後更新時間 2025/07/21 , 03:15 AM
負責人
Chun,Ming-Wei
統一編號
21251208
成立日期
1985/01/29
資本額
NT$100,000,000
實收資本額
NT$50,000,000
股票代號
電話
03-3268966
地址
4F, No. 2, Ln. 248, Sec. 1, Heping E. Rd., Da’an Dist., Taipei City, 106, Taiwan
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
Chun,Ming-Wei Chairman 0.00%
Peng,Pei-Ye Director 43.68%
Chen,Shu-Hua Director 0.00%
Liu,Zhen-Guo Supervisor 0.96%
營業項目
  • Real Estate Agencies Activities(681211)
  • Real Estate Agencies Activities(681212)
  • Real Estate Activities for Sale and Rental with Own or Leased Property(681112)
  • Management Consultancy Activities(702099)
  • 公司歷程
  • Change Person in Charge to Chun,Ming-Wei
    2023/07/31
  • Change Capital to 100,000,000
    2012/06/27
  • Change Person in Charge to Li,Bi-Hua
    2011/04/22
  • 員工人數
    下載完整報告查看完整數據
    財務報表
    動產抵押
    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額
    標案拒往
    機關名稱 生效日期 截止日期
    進出口資料
    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    商標
  • 房仲升格
  • AI 地產機器人
  • 台灣房屋交易所
  • 女人當家Woman設計圖
  • 台灣不動產
  • 台灣房屋仲介股份有限公司標章
  • 專利
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
  • Others
    2009, 2016, 2022, 2023, 2024
  • Rebate
    2010
  • Litigation aid
    2016
  • Return deposit
    2009
  • Stop execution
    2010
  • Price reduction
    2023
  • Fulfill contract
    2016
  • Pay severance pay
    2013, 2015
  • Promissory note ruling
    2008, 2009, 2014, 2015
  • Compensation for damage
    2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2020
  • Time-limited prosecution
    2009, 2010
  • Pay for liquidated damages
    2012, 2015
  • Rescission of contract, etc.
    2023, 2024
  • Compensation for damage, etc.
    2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024
  • Debt default compensation, etc
    2021
  • Infringement damage compensation
    2020
  • Restitution of unjust enrichment
    2019
  • Restitution of unjust enrichment, etc.
    2014
  • Confirmation of the non-existence of promissory note, etc
    2008
  • Others
    2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022
  • Payment order
    2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
  • Pay service fee
    2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2020, 2022
  • Pay remuneration
    2009, 2010, 2012, 2013, 2024
  • Pay severance pay
    2014
  • Waste Disposal Act
    2009
  • Promissory note ruling
    2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021
  • Compensation for damage
    2008, 2009, 2019
  • Pay for liquidated damages
    2009, 2011, 2016, 2017, 2019, 2024
  • Delivery of court audio CDs
    2014, 2015
  • Compensation for damage, etc.
    2014, 2015
  • Debt default compensation, etc
    2021, 2023
  • Request for damage compensation
    2019
  • Pay for liquidated damages, etc.
    2023
  • Restitution of unjust enrichment
    2020
  • Promissory note ruling enforcement
    2020
  • Act of Gender Equality in Employment
    2014, 2015
  • Request for damage compensation, etc.
    2016
  • Restitution of unjust enrichment, etc.
    2015
  • 勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。