翔譽國際建設股份有限公司 Approved
最後更新時間 2025/07/10 , 09:17 PM
最後更新時間 2025/07/10 , 09:17 PM
負責人
Zhang,Xiu-Qing
統一編號
27960157
成立日期
2005/10/17
資本額
NT$1,250,000,000
實收資本額
NT$1,192,800,000
股票代號
電話
地址
13F, No. 101, Sec. 1, Heping W. Rd., Nanfu Vil., Zhongzheng Dist., Taipei City, 100, Taiwan
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
Zhang,Xiu-Qing Chairman 99.66% XIN HAN ASSET CO., LTD.
Zhang,Xin-Xin Director 99.66% XIN HAN ASSET CO., LTD.
Xiao,Li-Zi Director 99.66% XIN HAN ASSET CO., LTD.
Wu,Ju-Lan Supervisor 0.00%
營業項目
  • Real Estate Activities for Sale and Rental with Own or Leased Property(681111)
  • Real Estate Development Activities(670012)
  • Building Completion and Finishing(434011)
  • 公司歷程
  • Change Capital to 1,250,000,000
    2024/07/30
  • Change Company Name to XIANG YU INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO., LTD.
    2022/12/20
  • Change Company Name to XIANGYU INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO., LTD. (FORMER NAME: XIANGYU CONSTRUCTION CO., LTD.)
    2022/02/08
  • Change Capital to 650,000,000
    2022/02/08
  • Change Capital to 600,000,000
    2021/08/12
  • 員工人數
    財務報表
    動產抵押
    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額
    標案拒往
    機關名稱 生效日期 截止日期
    進出口資料
    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    商標
  • 翔譽國際
  • 專利
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
  • Others
    2012, 2013, 2015, 2016
  • Pay price
    2016
  • Pay off debt
    2010, 2012, 2013
  • Rebate, etc.
    2017
  • Litigation aid
    2012
  • Pay commission
    2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Return deposit
    2016, 2017
  • Stop execution
    2012
  • Fulfill contract
    2012, 2013
  • National Remedy, etc.
    2011, 2012
  • Fulfill contract, etc.
    2013
  • Compensation for damage
    2012, 2017, 2020
  • Debtor objection appeal
    2013
  • Determine legal expenses
    2016
  • Third party objection suit
    2012, 2013
  • Pay construction fees, etc.
    2023
  • Restitution of unjust enrichment
    2014
  • Division of common property, etc.
    2022
  • Motion of objection (return of deposit)
    2011
  • Removal and restitution on real property
    2010
  • Cancellation of ownership transfer registration
    2011
  • Others
    2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022
  • Rebate, etc.
    2018
  • Payment order
    2011, 2012, 2014
  • Litigation aid
    2011, 2012, 2013
  • Pay commission
    2015, 2016
  • Return deposit
    2017
  • Fulfill contract
    2013
  • Rehearing action
    2011
  • Restitution, etc.
    2019
  • Petition for trial
    2013
  • Motion of objection
    2011
  • Pay for the project
    2021
  • Fulfill contract, etc.
    2013, 2014
  • Provisional attachment
    2017
  • Compensation for damage
    2011, 2012
  • Debtor objection appeal
    2013
  • Debt default compensation
    2010
  • Division of common property
    2010, 2013
  • Registration of land rights
    2016
  • Restitution of unjust enrichment
    2023
  • Request to fulfill contract, etc.
    2014
  • Registration of superficial rights
    2021, 2023
  • Appointment of estate administrators
    2011, 2012, 2013
  • Removal and restitution on real property
    2011
  • Removal and restitution on real property, etc.
    2010, 2011, 2012, 2013, 2015
  • Cancellation of the registration of land rights
    2014, 2015
  • 勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。