欣隆精密壓鑄股份有限公司 Approved
最後更新時間 2025/07/21 , 03:15 AM
最後更新時間 2025/07/21 , 03:15 AM
負責人
Huang,Zhen-Wen
統一編號
34176294
成立日期
1977/10/11
資本額
NT$500,000,000
實收資本額
NT$260,000,000
股票代號
電話
03-356-6558
地址
No. 206, Sec. 1, Minsheng N. Rd., Guishan Dist., Taoyuan City, 333, Taiwan
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
Huang,Zhen-Wen Chairman 20.31%
Huang,Jin-Yang Director 37.05%
Liu,Yu-Juan Director 4.54%
Han,Wei-Lun Supervisor 0.00%
營業項目
  • Casting of Aluminum(242211)
  • Manufacture of Other Fabricated Metal Products Not Elsewhere Classified(259999)
  • 公司歷程
  • Change Capital to 500,000,000
    2024/07/09
  • Change Person in Charge to Huang,Zhen-Wen
    2019/06/10
  • Change Person in Charge to
    2018/06/06
  • Change Person in Charge to Liu,Yan-Ming
    2018/05/21
  • Change Person in Charge to Liu,Jian-Long
    2017/03/03
  • Change Person in Charge to Liu,Yan-Ming
    2011/08/04
  • 員工人數
    下載完整報告查看完整數據
    財務報表
    動產抵押
    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額
    標案拒往
    機關名稱 生效日期 截止日期
    進出口資料
    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    商標
  • SHIN LONG
  • SL 設計圖
  • SHIN LONG
  • 專利
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
  • Others
    2013, 2021
  • Return stock
    2024
  • Return deposit
    2012, 2023
  • Auction collateral
    2019
  • Pay for the project
    2019, 2020
  • Provisional attachment
    2022, 2023
  • Pay severance pay, etc.
    2020, 2021
  • Appointment of inspectors
    2011, 2013
  • Adjudicate stock purchase price
    2023, 2024
  • Tort damages compensation, etc.
    2023
  • Appointment of interim administrators
    2019
  • Revocation of resolutions of shareholders' meeting
    2011, 2013, 2019, 2021
  • Confirmation that the resolution of the shareholders' meeting is invalid
    2019
  • Confirmation that the resolution of the shareholders' meeting is not established, etc.
    2023
  • Others
    2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023
  • Company Law
    2020, 2021, 2023
  • Payment order
    2019
  • Return seal stamp
    2020, 2022, 2023
  • Auction collateral
    2019
  • Petition for trial
    2022
  • Pay for the project
    2020
  • Invalidating Judgment
    2014, 2020
  • Provisional injunction
    2011
  • Compensation for damage
    2024
  • Pay severance pay, etc.
    2020
  • Time-limited prosecution
    2011
  • Appointment of inspectors
    2013
  • Delivery of court audio CDs
    2022
  • Adjudicate stock purchase price
    2023
  • Ownership transfer registration
    2004, 2005
  • Tort damages compensation, etc.
    2023
  • Infringement damage compensation
    2021, 2022, 2024
  • Petition filed for public summons
    2014, 2018, 2020
  • Profit-seeking Enterprise Income Tax
    2010, 2011, 2014
  • Restitution of unjust enrichment, etc.
    2015
  • Revocation of resolutions of shareholders' meeting
    2014, 2020, 2021, 2022
  • Confirmation that the resolution of the shareholders' meeting is invalid
    2019, 2021
  • 勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。