日南紡織股份有限公司 Approved
最後更新時間 2025/05/02 , 01:25 AM
最後更新時間 2025/05/02 , 01:25 AM
負責人
Lin,Ming-Chong
統一編號
56039219
成立日期
1970/09/14
資本額
NT$1,611,860,000
實收資本額
NT$1,611,860,000
股票代號
電話
04-26811111
地址
No. 29, Youshih Rd., Dajia Dist., Taichung City, 437, Taiwan
網站
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
Lin,Ming-Chong Chairman 16.17%
Lin,Ming-De Vice Chairman 14.29%
Lin,Ming-Zhou Managing Director 13.02%
Vacancy Director 0.00%
Xie,Shi-Fu Director 1.08%
Lai,Tai-Hua Director 0.02%
Li,Fu-Lu Director 0.02%
Li,Wen-Jun Director 0.00%
Ke,Jin-Kun Director 0.02%
Lin,Ya-Ling Supervisor 3.79%
Lin,Lie-Zhong Supervisor 0.21%
營業項目
  • Manufacture of Woven Cotton-type or Woolen-type Fabrics(112111)
  • Manufacture of Woven Cotton-type or Woolen-type Fabrics(112112)
  • 公司歷程
  • Change Person in Charge to Lin,Ming-Chong
    2019/02/22
  • 員工人數
    下載完整報告查看完整數據
    財務報表
    動產抵押
    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    存款不足之退票事宜
    時間 金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額
    標案拒往
    機關名稱 生效日期 截止日期
    進出口資料
    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    商標
  • 日南紡織股份有限公司標章
  • 日南
  • 南星
  • 日南牌(紅色)
  • 南星牌SOUTHERN CROSS (SC) (彩色)
  • 專利
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
  • Others
    2005, 2006, 2008, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  • Pay salary
    2008, 2009
  • Payment, etc.
    2007
  • Return deposit
    2008, 2009
  • Pay for pension
    2018
  • Pay service fee
    2005
  • Dispossessed, etc.
    2021, 2022
  • Pay for the project
    2003, 2007
  • Determine legal expenses
    2008, 2016, 2019, 2022
  • Pay management fees, etc.
    2022
  • Compensation for damage, etc.
    2018
  • Request for damage compensation
    2013, 2023
  • Demolition of ground features to return the land
    2009
  • Cancellation of ownership transfer registration, etc.
    2016
  • Fraud
    2005
  • Others
    2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
  • Fraud etc.
    2006
  • Business tax
    2015, 2016
  • Payment order
    2022
  • Litigation aid
    2015
  • Pay rent, etc.
    2020
  • Pay the ticket
    2002, 2007
  • Return deposit
    2010
  • Pay for pension
    2018, 2019
  • Fair Trading Act
    2006
  • Pay for the goods
    2000, 2002
  • Dispossessed, etc.
    2022
  • Return signing fee
    2014
  • Labor Standards Act
    2002, 2003, 2017
  • Pay for the project
    2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014
  • Promissory note ruling
    2007
  • Determine legal expenses
    2007, 2008, 2021, 2022
  • Pay management fees, etc.
    2022, 2023
  • Allotment Objection Appeal
    2010
  • Damage to reputation, etc.
    2006, 2007, 2008
  • Pay for liquidated damages
    2015, 2016, 2017
  • Request for liquidated damages
    2019
  • Request for damage compensation
    2007
  • Request for construction payment
    2010, 2013, 2014
  • Restitution of unjust enrichment
    2014, 2019, 2021
  • Profit-seeking Enterprise Income Tax
    2017, 2018
  • Cancellation of ownership transfer registration, etc.
    2020
  • Request for cancellation of ownership transfer registration, etc.
    2020
  • 勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。