台灣福斯財務服務股份有限公司 Approved
最後更新時間 2025/05/05 , 02:55 AM
最後更新時間 2025/05/05 , 02:55 AM
負責人
Pu,Long-Gen
統一編號
80305460
成立日期
2002/12/12
資本額
NT$200,000,000
實收資本額
NT$200,000,000
股票代號
電話
地址
16F, No. 1, Songgao Rd., Xinyi Dist., Taipei City, 110, Taiwan
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
Pu,Long-Gen Chairman 100.00% Volkswagen Finance Overseas B.V.
Olga Ryazantseva Director 100.00% Volkswagen Finance Overseas B.V.
Guilhermc Trinco Director 100.00% Volkswagen Finance Overseas B.V.
營業項目
  • Renting and Leasing of Motor Vehicles(772100)
  • Non-depository Financing(649699)
  • Retail Sale of Motor Vehicles in Specialized Stores(484112)
  • 公司歷程
  • Change Person in Charge to HolgerPruessner
    2023/07/06
  • Change Person in Charge to Ou Yang,Jin
    2021/03/23
  • Change Person in Charge to Dai,Rui-Fu
    2017/11/07
  • Change Capital to 200,000,000
    2016/12/02
  • 員工人數
    下載完整報告查看完整數據
    財務報表
    動產抵押
    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    存款不足之退票事宜
    時間 金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額
    標案拒往
    機關名稱 生效日期 截止日期
    進出口資料
    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    商標
    專利
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
  • Others
    2020
  • Stop execution
    2018, 2020, 2024
  • Return property
    2020, 2021
  • Stop enforcement
    2018
  • Installment event
    2023
  • Return of guarantee
    2020
  • Promissory note ruling
    2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023
  • Compensation for damage
    2011
  • Debtor objection appeal
    2010, 2018, 2019, 2020
  • Petition for enforced stopage
    2018
  • Return security deposit, etc.
    2022
  • Restitution of unjust enrichment
    2021
  • ruling of legal expenses ex officio
    2020
  • Confirmation of the non-existence of promissory note
    2008, 2011, 2015, 2016, 2024
  • Confirmation of the non-existence of promissory note, etc
    2018
  • Others
    2022, 2024
  • Disclaimer
    2012
  • Installment
    2020
  • Pay off debt
    2017, 2020, 2021
  • Payment order
    2020, 2021, 2022, 2023, 2024
  • Return property
    2017, 2021
  • Installment event
    2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2024
  • Liquidation event
    2022, 2024
  • Auction collateral
    2024
  • Invalidating Judgment
    2012
  • Promissory note ruling
    2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
  • Compensation for damage
    2012, 2020, 2021
  • Petition for disclaimer
    2018
  • Perform installment events
    2015, 2019
  • Perform liquidation events
    2017
  • Petition for reinstatement
    2013
  • Invalidating Judgment (Note)
    2012
  • Return security deposit, etc.
    2023
  • Pay the buying and selling price
    2021, 2022
  • Petition filed for public summons
    2007, 2012, 2014
  • Promissory note ruling enforcement
    2015
  • Cancellation of ownership transfer registration
    2023
  • Cancellation of ownership transfer registration, etc.
    2020
  • 勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。